Anexo:Localidades de Connecticut

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta lista comprende a todas las 142 localidades incorporadas en el estado estadounidense de Connecticut (sin incluir 169 pueblos), en la que incluye a las 20 ciudades (city), 10 boroughs y 112 lugares designados por el censo (CDP) con los datos del Censo de 2010 ordenados en orden alfabético:

Localidades[editar]

Mapa de EE. UU. & Connecticut
Bridgeport
Hartford.
New Haven Green.
Stamford
Quinnipiac River
Thames River
New London
Farmington
Mansfield
New Canaan
Wilton
Tolland
Weston
Pomfret
Salisbury
Kent
Nombre Entidad Censo de 2010
Ansonia ciudad 19249
Baltic CDP 1250
Bantam borough 759
Bethel CDP 9549
Bethlehem Village CDP 2021
Blue Hills CDP 2901
Branford Center CDP 5819
Bridgeport ciudad 144229
Bristol ciudad 60477
Broad Brook CDP 4069
Brooklyn CDP 981
Byram CDP 4146
Canaan CDP 1212
Cannondale CDP 141
Canton Valley CDP 1580
Cheshire Village CDP 5786
Chester Center CDP 1558
Clinton CDP 3368
Colchester CDP 4781
Collinsville CDP 3746
Conning Towers Nautilus Park CDP 8834
Cos Cob CDP 6770
Coventry Lake CDP 2990
Crystal Lake CDP 1945
Danbury ciudad 80893
Danielson borough 4051
Darien CDP 20732
Deep River Center CDP 2484
Derby ciudad 12902
Durham CDP 2933
East Brooklyn CDP 1638
East Hampton CDP 2691
East Hartford CDP 51252
East Haven CDP 29257
Essex Village CDP 2495
Falls Village CDP 538
Fenwick borough 43
Gales Ferry CDP 1162
Georgetown CDP 1805
Glastonbury Center CDP 7387
Glenville CDP 2327
Greenwich CDP 12942
Groton ciudad 10389
Groton Long Point borough 518
Guilford Center CDP 2597
Hartford ciudad 124775
Hazardville CDP 4599
Heritage Village CDP 3736
Higganum CDP 1698
Jewett City borough 3487
Kensington CDP 8459
Lake Pocotopaug CDP 3436
Lakeville CDP 928
Litchfield borough 1258
Long Hill CDP 4205
Madison Center CDP 2290
Manchester CDP 30577
Mansfield Center CDP 947
Mashantucket CDP 299
Meriden ciudad 60868
Middletown ciudad 47648
Milford ciudad 52759
Moodus CDP 1413
Moosup CDP 3231
Mystic CDP 4205
Naugatuck borough 31862
New Britain ciudad 73206
New Hartford Center CDP 1385
New Haven ciudad 129779
Newington CDP 30562
New London ciudad 27620
New Milford CDP 6523
New Preston CDP 1182
Newtown borough 1941
Niantic CDP 3114
Noank CDP 1796
Norfolk CDP 553
North Granby CDP 1944
North Grosvenor Dale CDP 1530
North Haven CDP 24093
Northwest Harwinton CDP 3252
Norwalk ciudad 85603
Norwich ciudad 40493
Oakville CDP 9047
Old Greenwich CDP 6611
Old Mystic CDP 3554
Old Saybrook Center CDP 2039
Orange CDP 13956
Oxoboxo River CDP 3165
Pawcatuck CDP 5624
Pemberwick CDP 3680
Plainfield Village CDP 2557
Poquonock Bridge CDP 1727
Portland CDP 5862
Putnam CDP 7214
Quinebaug CDP 1133
Ridgefield CDP 7645
Riverside CDP 8416
Rockville CDP 7474
Salmon Brook CDP 2324
Saybrook Manor CDP 1052
Sharon CDP 729
Shelton ciudad 39559
Sherwood Manor CDP 5410
Simsbury Center CDP 5836
Somers CDP 1789
South Coventry CDP 1483
Southport CDP 1585
South Windham CDP 1421
Southwood Acres CDP 7657
South Woodstock CDP 1291
Stafford Springs CDP 4988
Stamford ciudad 122643
Stonington borough 929
Storrs CDP 15344
Stratford CDP 51384
Suffield Depot CDP 1325
Tariffville CDP 1324
Terramuggus CDP 1025
Terryville CDP 5387
Thomaston CDP 1910
Thompsonville CDP 8577
Torrington ciudad 36383
Trumbull CDP 36018
Wallingford Center CDP 18209
Waterbury ciudad 110366
Waterford CDP 2887
Watertown CDP 3574
Wauregan CDP 1205
Weatogue CDP 2776
Westbrook Center CDP 2413
West Hartford CDP 63268
West Haven ciudad 55564
Westport CDP 26391
West Simsbury CDP 2447
Wethersfield CDP 26668
Willimantic CDP 17737
Wilton Center CDP 732
Windsor Locks CDP 12498
Winsted CDP 7712
Woodbury Center CDP 1294
Woodmont borough 1488

Véase también[editar]

Referencias[editar]